Thea v. Kleinhandler ( 2015 )


Menu:
  • 14‐3201
    Thea v. Kleinhandler
    UNITED STATES COURT OF APPEALS
    FOR THE SECOND CIRCUIT
    August Term 2014
    (Argued: March 26, 2014                         Decided: November 3, 2015)
    Docket No. 14‐3201
    DONALD M. THEA, DEBORAH L. THEA,
    Plaintiffs‐Appellants,
    v.
    NEIL C. KLEINHANDLER, As Trustee of the Frederica Fisher Thea Revocable
    Trust, NEW SCHOOL UNIVERSITY, ERIC T. SCHNEIDERMAN, Attorney General of
    the State of New York,
    Defendants‐Appellees.
    ON APPEAL FROM THE UNITED STATES DISTRICT COURT
    FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK
    Before:
    JACOBS and CHIN, Circuit Judges,
    and WOLFORD, District Judge.*
    *     The Honorable Elizabeth A. Wolford, of the Western District of New York,
    sitting by designation.
    Appeal from a judgment of the United States District Court for the
    Southern District of New York (Castel, J.), denying plaintiffsʹ motion for leave to
    file a second amended complaint.  The district court concluded that allowing
    plaintiffs to amend their complaint would be futile, because they lacked standing
    to sue in their individual capacities and their claims on behalf of the estate were
    time‐barred under Californiaʹs one‐year statute of limitations.  We affirm on the
    grounds that all the claims are time‐barred.
    AFFIRMED.
    ANTHONY J. VIOLA (Zachary W. Silverman, on the brief),
    Edwards Wildman Palmer LLP, New York, New
    York, for Plaintiffs‐Appellants.
    BRUCE J. TURKLE (Perry S. Galler, on the brief), Phillips
    Nizer LLP, New York, New York, for Defendant‐
    Appellee Neil C. Kleinhandler, Individually and as
    Trustee of the Frederica Fisher Thea Revocable Trust.
    MARCY RESSLER HARRIS, Schulte Roth & Zabel LLP,
    New York, New York, for Defendant‐Appellee New
    School University.
    JASON HARROW, Assistant Solicitor General (Barbara D.
    Underwood, Solicitor General, and Claude S.
    Platton, Assistant Solicitor General, on the brief),
    for Eric T. Schneiderman, Attorney General of the
    State of New York, New York, New York, for
    Defendant‐Appellee Attorney General of the State of
    New York.
    ‐2‐
    CHIN, Circuit Judge:
    In this case, Stanley Thea (ʺStanleyʺ) and Frederica Thea
    (ʺFredericaʺ) agreed to and did execute mutual wills providing for each otherʹs
    assets to pass to the survivor and, upon the death of the survivor, to Stanleyʹs
    children from a prior marriage, Donald Thea and Deborah Thea (the ʺTheasʺ).
    After Stanley died, however, Frederica transferred substantially all of her assets
    to a trust (the ʺTrustʺ), leaving the remainder interest not to the Theas but to
    defendant‐appellee New School University (the ʺNew Schoolʺ).
    The Theas commenced this action against the New School as well as
    defendants‐appellees Neil Kleinhandler, as trustee of the Trust, and Eric
    Schneiderman, as Attorney General of New York, contending that they were
    entitled to the Trustʹs assets and seeking, inter alia, declaratory and equitable
    relief.  On May 12, 2014, the district court dismissed the Theasʹ claims without
    prejudice, on the grounds that it was unable to adjudicate the claims because no
    representative of Fredericaʹs estate (the ʺEstateʺ) was a party to the action.  After
    being appointed special administrators of the Estate, the Theas sought leave to
    file a second amended complaint.  On August 1, 2014, the district court denied
    the Theasʹ motion on grounds of futility, concluding that the claims alleged in the
    ‐3‐
    proposed second amended complaint would not withstand a motion to dismiss.
    The Theas appeal.  We affirm.
    BACKGROUND
    A.         The Facts
    For the purposes of this appeal, the facts alleged in the proposed
    second amended complaint are assumed to be true.  They may be summarized as
    follows:
    The Theas are the only children of Stanley and his first wife.  In 1985,
    Stanley married his third wife, Frederica.  Stanley and Frederica had no children
    together.  On April 13, 1995, Stanley and Frederica entered into an agreement
    (the ʺAgreementʺ) to execute mutual wills providing that the surviving spouse
    would receive the deceased spouseʹs property and, upon the surviving spouseʹs
    death, the surviving spouseʹs property would pass to the Theas.1  Stanley and
    1              Fredericaʹs will provided in pertinent part that:  ʺI give and bequeath all
    the household and personal effects, including jewelry, clothing, pictures, objects of art,
    and automobiles belonging to me at my death, together with all insurance policies
    relating thereto, to my husband, STANLEY THEA, if he survives me.  If my husband,
    STANLEY THEA, shall predecease me then I give and bequeath such household and
    personal effects in equal shares to his son DONALD MARK THEA and his daughter
    DEBORAH LOUISE THEA, or to the survivor of them. . . .  I give, devise, and bequeath
    all the residue and remainder of my estate of whatsoever kind and wheresoever situate
    to my husband, STANLEY THEA, if he survives me, but if he predeceases me, in equal
    shares to his issue [] surviving [me], per stirpes.ʺ
    ‐4‐
    Frederica executed wills in accordance with the Agreement.  Fredericaʹs will
    provides that when Stanley died, the Theas would be the sole executors.
    Stanley predeceased Frederica in 1998.  Thus, in accordance with
    Stanleyʹs will and the Agreement, Frederica inherited Stanleyʹs assets, including
    two apartments in New York City ‐‐ one in Manhattan and one in Astoria.  Neil
    Kleinhandler and his firm represented Frederica in connection with the probate
    of Stanleyʹs estate.
    In December 2002, Frederica created the Trust, which was governed
    by New York law and was revocable.  Frederica and Kleinhandler were
    designated as co‐trustees.  The New School, a university based in New York City,
    was designated as the sole remainder beneficiary of the Trust.  On or about
    December 17, 2002, Frederica transferred the New York City apartments and
    substantially all of her other property and assets into the Trust.  For the
    remainder of Fredericaʹs life, the Trust managed the assets for her benefit.
    In 2007, the Trust sold the Manhattan apartment for approximately
    $1.65 million.  The Astoria apartment was also sold for an undisclosed amount.
    The proceeds of both apartments remained in the Trust.  On or about June 15,
    2011, the Trust purchased a residence in Carmel, California for approximately
    $1.9 million.  Frederica moved into the Carmel residence and resided there for
    ‐5‐
    the remainder of her life.  The Trust also owns securities and capital, located in
    various bank and brokerage accounts in New York, valued at approximately
    $500,000.
    On February 4, 2012, Frederica died of an apparent suicide.  Law
    enforcement officials discovered a suicide note with instructions to contact
    Kleinhandler, her real estate agent, and her accountant.  After Kleinhandler was
    notified of Fredericaʹs death, he represented to law enforcement officials that he
    was authorized to act on behalf of the Estate.
    Kleinhandler did not inform the Theas of their stepmotherʹs death,
    nor did he publish an obituary or otherwise publicize her passing. 2  Within a
    week of Fredericaʹs death, the Carmel residence was listed for sale with a real
    estate broker, but it has not been sold.  The Theas have not received any Trust
    assets.
    B.         Proceedings Below
    On July 15, 2013, the Theas, in their individual capacities,
    commenced this action against Kleinhandler, as the sole trustee of the Trust.3
    2             The proposed second amended complaint is silent as to when the Theas
    learned of Fredericaʹs death.  They represent in their brief on appeal that they did not
    learn of her death until more than a year later, in May 2013.
    3             The Theas invoked the district courtʹs diversity jurisdiction, alleging that
    Donald Thea was a citizen of Massachusetts, Deborah Thea a citizen of California, and
    ‐6‐
    The Theas alleged that Frederica had defeated the intent of the Agreement by
    transferring her assets to the Trust.
    On August 27, 2013, after limited discovery, the Theas served an
    amended complaint, naming two new defendants: the New School, as the Trustʹs
    remainder beneficiary, and the Office of the New York State Attorney General.4
    The amended complaint also included a claim for breach of fiduciary duty
    against Kleinhandler, both individually and as trustee of the Trust.
    On October 7, 2013, Kleinhandler and the New School moved to
    dismiss the amended complaint pursuant to Fed. R. Civ. P. 12(b)(6).  On May 13,
    2014, the district court granted, without prejudice, the motions on the grounds
    that it was unable to fully adjudicate the Theasʹ claims until a representative of
    the Estate was appointed and joined as a necessary party.  The district court held
    that an administrator or executor of the Estate could seek leave to amend within
    21 days of the May 13 order.
    Kleinhandler a citizen of New York.  See 28 U.S.C. § 1332(a).  The parties do not contest
    jurisdiction.
    4               The Attorney General appears in his capacity as statutory representative
    of the beneficiaries of ʺdispositions for religious, charitable, educational or benevolent
    purposes and it shall be his duty to enforce the rights of such beneficiaries by
    appropriate proceedings in the courts.ʺ  N.Y. Est. Powers & Trusts Law § 8‐1.1(f)
    (McKinney 2010).
    ‐7‐
    The Theas immediately initiated probate proceedings in the
    Superior Court of California, County of Monterey, seeking to be appointed
    representatives of the Estate.  The Theas filed an expedited petition for ʺLetters of
    Special Administrationʺ so that their application could be heard prior to the 21‐
    day deadline imposed by the district court in this case.  On May 28 and May 30,
    2014, the California court granted the Theasʹ request, issuing Letters of Special
    Administration to both of them.  The California court also admitted Fredericaʹs
    will to probate.
    On June 2, 2014, the Theas sought leave to file a second amended
    complaint, in their individual capacities, as creditors of the Estate, and as special
    administrators of the Estate.  The Theas asserted claims in: (1) their individual
    capacity; (2) their capacity as creditors of the Estate; and (3) their capacity as
    special administrators of the Estate.
    On August 1, 2014, the district court denied the Theasʹ motion for
    leave to amend on grounds of futility, concluding that the claims alleged in the
    proposed second amended complaint would not withstand a motion to dismiss.
    First, the district court rejected the Theasʹ individual claims for lack of standing.
    Second, the district court applied New Yorkʹs borrowing statute, N.Y. C.P.L.R.
    202, to the Theasʹ claims as special administrators.  It concluded that California
    ‐8‐
    law applied to these claims, and then held that all of the Theasʹ claims on behalf
    of the Estate were time‐barred because they were governed by a one‐year statute
    of limitations pursuant to § 366.3 of the California Code of Civil Procedure.  The
    district court also held that the Theas did not allege sufficient facts to conclude
    that equitable estoppel could toll their time to file.  Last, the district court held
    that because the underlying claims against Kleinhandler and the Trust were
    untimely, the Theas remaining claims would not withstand a motion to dismiss.
    Thus, the district court held that allowing the Theas to amend to add these
    remaining claims would also be futile.  Judgment was entered in favor of
    defendants on August 4, 2014.
    This appeal followed.
    DISCUSSION
    I.       Standard of Review
    We generally review a district courtʹs denial of leave to amend for
    abuse of discretion, ʺkeeping in mind that leave to amend should be freely
    granted when ʹjustice so requires.ʹʺ  Sista v. CDC Ixis N. Am., Inc., 445 F.3d 161,
    177 (2d Cir. 2006) (quoting Pangburn v. Culbertson, 200 F.3d 65, 70 (2d Cir. 1999)).
    A district court abuses its discretion if it bases its ruling on ʺan erroneous view
    of the law, a clearly erroneous assessment of the facts, or a decision that cannot
    ‐9‐
    be located within the range of permissible decisions.ʺ  Anderson News, L.L.C. v.
    Am. Media, Inc., 680 F.3d 162, 185 (2d Cir. 2012).  Where the denial of leave to
    amend is based on the resolution of legal questions, however, ʺa reviewing court
    conducts a de novo review.ʺ  Hutchison v. Deutsche Bank Sec. Inc., 647 F.3d 479, 490
    (2d Cir. 2011).
    The district court denied leave to the Theas to file the proposed
    second amended complaint on grounds of futility, concluding that it would not
    withstand a motion to dismiss.  Thea v. Kleinhandler, No. 13‐CV‐4895 (PKC), 2014
    WL 3812231, at  *6, *9 (S.D.N.Y. Aug. 1, 2014); see also Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S.
    662, 678 (2009) (to survive motion to dismiss, ʺa complaint must contain
    sufficient factual matter, accepted as true, to ʹstate a claim to relief that is
    plausible on its faceʹʺ (quoting Bell Atl. Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544, 570
    (2007)).  ʺProposed amendments are futile if they ʹwould fail to cure prior
    deficiencies or to state a claim under Rule 12(b)(6) of the Federal Rules of Civil
    Procedure.ʹʺ  IBEW Local Union No. 58 Pension Trust Fund & Annuity Fund v.
    Royal Bank of Scotland Grp., PLC, 783 F.3d 383, 389 (2d Cir. 2015) (quoting Panther
    Partners Inc. v. Ikanos Commcʹns, Inc., 681 F.3d 114, 119 (2d Cir. 2012)).  Here, the
    district courtʹs conclusion that the proposed amended pleading failed to state a
    claim, and thus would not survive a motion to dismiss, was a legal
    ‐10‐
    determination.  See Panther Partners Inc., 681 F.3d at 119 (ʺFutility is a
    determination, as a matter of law, that proposed amendments would fail . . . to
    state a claim.ʺ).  Thus, the applicable standard of review here is de novo.  See, e.g.,
    Adelson v. Harris, 774 F.3d 803, 807 (2d Cir. 2014) (reviewing de novo district
    courtʹs dismissal under Rule 12(b)(6)); Gorman v. Consol. Edison Corp., 488 F.3d
    586, 591‐592 (2d Cir. 2007) (reviewing de novo district courtʹs denial of motions
    for leave to amend as futile).
    II.        Timeliness
    The district court held that a California one‐year statute of
    limitations governs this case and dismissed the Theasʹ claims on behalf of the
    Estate as time‐barred.  The Theas argue that this was error, and that a New York
    six‐year statute of limitations applies.5  We conclude that the one‐year California
    statute of limitations applies to all the claims in this action and that the Theasʹ
    claims are time‐barred.  We reject the Theasʹ contention that their claims are
    saved by the doctrine of equitable estoppel.
    5
    The district court also held that the Theas lacked standing to assert claims
    individually.  The Theas contend that the district court erred in this respect.  We do not
    reach this issue, in light of our ruling below on the timeliness of their claims.
    ‐11‐
    A.         Choice‐of‐Law Rules
    Where jurisdiction is predicated on diversity of citizenship, a federal
    court must apply the choice‐of‐law rules of the forum state.  Forest Park Pictures v.
    Universal Television Network, Inc., 683 F.3d 424, 433 (2d Cir. 2012); see also Klaxon
    Co. v. Stentor Elec. Mfg. Co., 313 U.S. 487, 496 (1941).  Under New York law, we
    apply the rules of decision that are considered ʺsubstantive,ʺ see Erie R. Co. v.
    Tompkins, 304 U.S. 64, 78 (1938),6 including statutes of limitation.  See Cantor
    Fitzgerald Inc. v. Lutnick, 313 F.3d 704, 710 (2d Cir. 2002) (ʺA stateʹs rules
    providing for the start and length of the statute of limitations is substantive
    law.ʺ); accord Stuart v. Am. Cyanamid Co., 158 F.3d 622, 626 (2d Cir. 1998) (ʺWhere
    jurisdiction rests upon diversity of citizenship, a federal court sitting in New
    York must apply the New York choice‐of‐law rules and statutes of limitations.ʺ).
    New Yorkʹs borrowing statute, N.Y. C.P.L.R. 202, provides that
    ʺwhen a nonresident plaintiff sues upon a cause of action that arose outside of
    New York, the court must apply the shorter limitations period, including all
    relevant tolling provisions, of either: (1) New York; or (2) the state where the
    cause of action accrued.ʺ  Stuart, 158 F.3d at 627; see Glob. Fin. Corp. v. Triarc Corp.,
    6              Whether a particular state rule of decision is ʺsubstantiveʺ is a question of
    federal law.  See Hanna v. Plumer, 380 U.S. 460, 465‐66 (1965).
    ‐12‐
    93 N.Y.2d 525, 528 (1999) (ʺWhen a nonresident sues on a cause of action
    accruing outside New York, CPLR 202 requires the cause of action to be timely
    under the limitation periods of both New York and the jurisdiction where the
    cause of action accrued.ʺ).7  New York follows ʺthe traditional definition of
    accrual ‐‐ a cause of action accrues at the time and in the place of the injury.ʺ
    Glob. Fin. Corp., 93 N.Y.2d at 529.  Where the ʺinjury is purely economic, the place
    of injury usually is where the plaintiff resides and sustains the economic impact
    of the loss.ʺ  Id.
    Under California law, ʺ[i]f a person has a claim that arises from a
    promise or agreement with a decedent to distribution from an estate or trust or
    under another instrument . . . an action to enforce the claim to distribution may
    be commenced within one year after the date of death, and the limitations period
    that would have been applicable does not apply.ʺ  Cal. Civ. Proc. Code § 366.3(a);
    see Allen v. Stoddard, 152 Cal. Rptr. 3d 71, 74 (Ct. App. 2013) (ʺSection 366.3 gives
    persons who have claims against estates based on promises to make a
    7             N.Y. C.P.L.R. 202 provides:  ʺAn action based upon a cause of action
    accruing without the state cannot be commenced after the expiration of the time limited
    by the laws of either the state or the place without the state where the cause of action
    accrued, except that where the cause of action accrued in favor of a resident of the state
    the time limited by the laws of the state shall apply.ʺ  See also In re Coudert Bros. LLP, 673
    F.3d 180, 190 (2d Cir. 2012) (noting that N.Y. C.P.L.R. 202 ʺguards against forum
    shopping by out‐of‐state plaintiffs by mandating use of the shortest statute of limitations
    availableʺ).
    ‐13‐
    distribution after death (such as contracts to make a will) a full year from the
    date of the decedentʹs death to file suit.ʺ).  Moreover, § 366.3 ʺhas been construed
    to ʹreach any action predicated upon the decedentʹs agreement to distribute
    estate or trust property in a specified manner.ʹʺ  In re Estate of Ziegler, 114 Cal.
    Rptr. 3d 863, 868 (Ct. App. 2010) (quoting Ferraro v. Camarlinghi, 75 Cal. Rptr. 3d
    19, 57 (Ct. App. 2008)).
    Under New York law, ʺ[a] disposition in trust for the use of the
    creator is void as against the existing or subsequent creditors of the creator.ʺ  N.Y.
    Est. Powers & Trusts Law § 7‐3.1 (McKinney 2005).  Claims under this statute are
    likely subject to the six‐year statute of limitations in N.Y. C.P.L.R. 213.  Cf. State v.
    Cetero, 233 A.D.2d 580, 582 (N.Y. App. Div. 3d Depʹt 1996) (noting that six‐year
    statute of limitations would apply where plaintiff attempted to set aside two
    provisions in trust agreement).  N.Y. C.P.L.R. 213 is a catch‐all provision that
    ʺrequires ʹan action for which no limitations is specifically prescribed by lawʹ to
    be brought within six years of a claimʹs accrual.ʺ  Melcher v. Greenberg Traurig,
    LLP, 23 N.Y.3d 10, 13 (2014) (quoting N.Y. C.P.L.R. 213(1) (McKinney 2004)).  As
    N.Y. Est. Powers & Trusts Law § 7‐3.1 does not specifically prescribe a statute of
    limitations period, New York courts have required actions commenced under
    ‐14‐
    this statute to be brought within six years.  See Christopher v. Tomeck, 82 A.D.3d
    1307, 1309 (N.Y. App. Div. 3d Depʹt 2011).
    B.     Applicability of Californiaʹs Statute of Limitations
    Here, the California statute applies to the Theasʹ claims.  While the
    district court did not apply the statute of limitations to the Theasʹ individual
    claims (which it rejected on standing grounds), we conclude that all the Theasʹ
    claims are time‐barred.
    First, the Theas, as administrators of the Estate, are deemed to be
    citizens of California.  See 28 U.S.C. § 1332(c)(2) (ʺthe legal representative of the
    estate of a decedent shall be deemed to be a citizen only of the same State as the
    decedentʺ).  Nor are they, in their individual capacities, citizens of New York, as
    Deborah is a California resident and Donald is a resident of Massachusetts.
    Second, the Theasʹ claims accrued in California.  The Theas allege
    that Kleinhandler and the Trust improperly exercised dominion and control over
    the Estateʹs assets.  Frederica was residing in California when she died.  The
    Estateʹs assets (consisting largely of Trust assets) were located primarily in
    California.  Thus, to the extent the Estate suffered economic harm, it did so in
    California.  To the extent the Theas suffered harm in their individual capacities
    ‐15‐
    or as creditors, it was not in New York but in California for Deborah and in
    Massachusetts for Donald.8
    Third, the California statute of limitations is the shorter of the two
    conflicting statutes, and New York Law requires that an action accruing outside
    the state must meet the statutes of limitations of both jurisdictions.  See Ins. Co. of
    N. Am. v. ABB Power Generation, Inc., 91 N.Y.2d 180, 187 (1997) (ʺCPLR 202
    requires that a court, when presented with a cause of action accruing outside
    New York, should apply the limitation period of the foreign jurisdiction if it bars
    the claim.ʺ).
    California law provides that any action arising ʺfrom a promise or
    agreement with a decedent to distribution from an estateʺ is subject to a one‐year
    statute of limitations period.  See Cal. Civ. Proc. Code § 366.3(a) (West 2010);
    Stewart v. Seward, 56 Cal. Rptr. 3d 651, 656‐59 (Ct. App. 2007) (applying § 366.3
    where plaintiff sought to enforce a promise to make a testamentary disposition).
    All the Theasʹ claims here arise from such a promise or agreement.  Hence, it
    appears that under New Yorkʹs borrowing statute, the one‐year California statute
    of limitations controls this action.
    8
    Like California law, Massachusetts law provides that an action against a
    decedent must be commenced within one year of the date of death.  Mass. Gen. Laws
    ch. 190B, § 3‐803 (West 2012).
    ‐16‐
    The Theas argue that § 366.3 applies only to claims against an estate
    and not on behalf of an estate.  The plain language of § 366.3, however, does not
    contemplate this distinction.  In fact, California courts have repeatedly construed
    § 366.3 to ʺreach any action predicated upon the decedentʹs agreement to
    distribute estate or trust property in a specified manner.ʺ  In re Estate of Ziegler,
    114 Cal. Rptr. 3d at 868 (quoting Ferraro, 75 Cal. Rptr. 3d at 57) (emphasis
    added)); McMackin v. Ehrheart, 122 Cal. Rptr. 3d 902, 909 (Ct. App. 2011)
    (applying § 366.3 to individual claim against estate).  Indeed, the Theasʹ claims
    arise from an agreement between Stanley and Frederica to a distribution from an
    estate ‐‐ the estate remaining, as it turned out, upon Fredericaʹs death.9
    The Theas further argue that New Yorkʹs longer statute of
    limitations applies to their claims because their claims relate to the transfer of
    property in New York ‐‐ Frederica lived in New York when she transferred
    substantially all of her property into the Trust.  In essence, they contend that
    their claims arose in New York and not California.  We reject this argument.
    First, even assuming Frederica transferred the assets into the Trust
    when she still lived in New York, there was nothing in the Agreement to prevent
    9             Moreover, § 366.3 has been applied to fraud and unjust enrichment claims
    and ʺto claims based on a contract to leave certain property by will, even when the
    claimant is seeking only damages for breach of the contract and is not seeking the
    property itself.ʺ  In re Estate of Ziegler, 114 Cal. Rptr. 3d at 868.
    ‐17‐
    her from doing so.  The Agreement ‐‐ and the mutual wills attached thereto ‐‐
    imposed no restrictions on her use of the assets during her lifetime.  She could
    have consumed all of the assets during her lifetime.  Second, the Trust used a
    substantial portion of its assets to purchase the home in Carmel, California, and
    Frederica moved there from New York in 2011 and resided there, in California,
    until her death on February 4, 2012.  Hence, the Trustʹs assets were substantially
    moved to California while Frederica was still alive.  Third, the only claim the
    Theas could have to the Trust assets arose only upon Fredericaʹs death, when she
    was residing in California and her assets were substantially located there as well.
    To the extent the Estate suffered an injury, the claim arose in California, where
    Frederica was residing at the time of her death.  To the extent the Theas suffered
    economic injuries, they did not do so in New York, as neither was a resident of
    New York.
    We therefore conclude that N.Y. C.P.L.R. 202 requires the
    application of Californiaʹs Code of Civil Procedure § 366.3 because it provides the
    shorter limitations period.  See Stuart, 158 F.3d at 627 (Under New York law, ʺthe
    court must apply the shorter statute of limitations period . . . of either: (1) New
    York; or (2) the state where the cause of action accrued.ʺ (citing N.Y. C.P.L.R. 202)
    (McKinney 2004).
    ‐18‐
    Frederica died on February 4, 2012 and this action was commenced
    on July 15, 2013, more than one year after her death.  Accordingly, it appears
    from the face of the proposed second amended complaint that the Theasʹ claims
    are time‐barred.
    C.         Equitable Estoppel
    The Theas contend that, even if § 366.3 applies to their claims,
    Kleinhandler should be equitably estopped from asserting the statute of
    limitations as a defense.  When applying another stateʹs statute of limitations
    pursuant to N.Y. C.P.L.R. 202, ʺ[a]ll the extensions and tolls applied in the
    foreign state must be imported with the foreign statutory period, so that the
    entire foreign statute of limitations . . .  applie[s], and not merely its period.ʺ
    Smith Barney, Harris Upham & Co. v. Luckie, 85 N.Y.2d 193, 207 (1995) (internal
    quotation marks omitted); see also Antone v. Gen. Motors Corp., Buick Motor Div.,
    64 N.Y.2d 20, 31 (1984) (ʺIt is true that in ʹborrowingʹ a Statute of Limitations of
    another State, a New York court will also ʹborrowʹ the other Stateʹs rules as to
    tolling.ʺ).10  Therefore, to the extent California law provides relief under an
    equitable estoppel theory, we apply it accordingly.
    10            We note that § 366.3 expressly circumscribes tolling and extension: ʺ[t]he
    limitations period provided in this section for commencement of an action shall not be
    tolled or extended for any reason . . . .ʺ  Cal. Civ. Proc. Code § 366.3(b).  California
    ‐19‐
    1.         Applicable Law
    Under California law, the doctrine of equitable estoppel may be
    applied, after the limitations period has run, to preclude a defendant from
    asserting the statute of limitations as a defense ʺwhere the partyʹs conduct has
    induced another into forbearing to file suit.ʺ  McMackin, 122 Cal. Rptr. 3d at 913;
    accord Doheny Park Terrace Homeowners Assʹn, Inc. v. Truck Ins. Exch., 34 Cal. Rptr.
    3d 157, 165 (Ct. App. 2005).  ʺReliance by the party asserting the estoppel on the
    conduct of the party to be estopped must have been reasonable under the
    circumstances.  ʹTo warrant reliance, a representation must be such as would
    induce a reasonable man to act upon it.ʹʺ  Mills v. Forestex Co., 134 Cal. Rptr. 2d
    273, 298 (Ct. App. 2003) (quoting Three Sixty Five Club v. Shostak, 104 Cal. App. 2d
    735, 739 (1951)).
    ʺThe elements of equitable estoppel are:  (1) the party to be estopped
    must be apprised of the facts; (2) that party must intend that his or her conduct
    be acted on, or must so act that the party asserting the estoppel had a right to
    believe it was so intended; (3) the party asserting the estoppel must be ignorant
    courts, however, distinguish between equitable tolling and equitable estoppel and have
    applied the latter under § 366.3.  See Lantzy v. Centex Homes, 73 P.3d 517, 533 (Cal. 2003)
    (ʺ[E]quitable estoppel is available even where the limitations statute at issue expressly
    precludes equitable tolling.ʺ).  We assume for the purposes of this appeal that
    Californiaʹs equitable estoppel doctrine applies under § 202.
    ‐20‐
    of the true state of facts; and (4) the party asserting the estoppel must reasonably
    rely on the conduct to his or her injury.ʺ  Honig v. San Francisco Planning Depʹt, 25
    Cal. Rptr. 3d 649, 655 (Ct. App. 2005) (citing Mills, 134 Cal. Rptr. 2d at 298).
    ʺAlthough the statute of limitations is ordinarily an affirmative
    defense that must be raised in the answer, a statute of limitations defense may be
    decided on a Rule 12(b)(6) motion if the defense appears on the face of the
    complaint.ʺ  Ellul v. Congregation of Christian Bros., 774 F.3d 791, 798 n.12 (2d Cir.
    2014) (citing Staehr v. Hartford Fin. Servs. Grp., Inc., 547 F.3d 406, 425 (2d Cir.
    2008)).  When a plaintiff relies on a theory of equitable estoppel to save a claim
    that otherwise appears untimely on its face, the plaintiff must specifically plead
    facts that make entitlement to estoppel plausible (not merely possible).  See
    Ashcroft, 556 U.S. at 678‐79; Twombly, 550 U.S. at 556‐57, 570.
    2.     Application
    The Theas argue that Kleinhandler should be estopped from
    invoking Californiaʹs § 366.3 statute of limitations, alleging the following facts:
    (1) Kleinhandler failed to disclose Fredericaʹs death to them, with the intent to
    conceal it; (2) Kleinhandler held himself out to law enforcement officials as the
    sole representative of the Estate; and (3) Kleinhandler had a duty, as trustee of
    the Trust, to disclose Fredericaʹs death.
    ‐21‐
    Under California law, however, equitable estoppel is only available
    where a defendant induces a plaintiff to forbear from filing suit.  See Prudential‐
    LMI Commercial Ins. v. Superior Court, 798 P.2d 1230, 1240 (Cal. 1990) (ʺ[Equitable]
    estoppel arises as a result of some conduct by the defendant, relied on by the
    plaintiff, which induces the belated filing of the action.ʺ  (internal quotation
    marks omitted)).11  That is, to be equitably estopped, a defendant must have
    taken affirmative steps to induce the plaintiff to refrain from filing a timely suit.
    See Vaca v. Wachovia Mortg. Corp., 129 Cal. Rptr. 3d 354, 360 (Ct. App. 2011) (ʺFor
    a defendant to be equitably estopped from asserting a statute of limitations, the
    plaintiff must be directly prevented . . . from filing [a] suit on time.ʺ  (internal
    quotation marks omitted)); Becerra v. Gonzales, 38 Cal. Rptr. 2d 248, 256 (Ct. App.
    1995) (ʺGenerally, estoppel arises from a partyʹs affirmative conduct which has
    led the opposing party to believe a particular fact is true, and to rely on that fact
    to his or her detriment.ʺ).
    11             Similarly, under New York law, equitable estoppel is available only where
    the plaintiff knew of the existence of the cause of action, but the defendantʹs misconduct
    caused the plaintiff to delay in bringing suit.  See, e.g., Green v. Albert, 199 A.D.2d 465
    (N.Y. App. Div. 2d Depʹt 1993); Murphy v. Wegmanʹs Food Mkt., 140 A.D.2d 973 (N.Y.
    App. Div. 4th Depʹt 1988); Buttry v. Gen. Signal Corp., 68 F.3d 1488, 1493 (2d Cir. 1995);
    Netzer v. Continuity Graphic Assocs., Inc., 963 F. Supp. 1308, 1316 (S.D.N.Y. 1997).
    Equitable tolling, on the other hand, is ʺavailable where the defendant has wrongfully
    deceived or misled the plaintiff to conceal the existence of a cause of action.ʺ  Kotlyarsky
    v. New York Post, 195 Misc. 2d 150, 153 (Sup. Ct. Kings Cty. 2003).
    ‐22‐
    Here, the Theas have failed to allege facts to plausibly suggest that
    Kleinhandler induced them to refrain from filing their action in a timely fashion.
    See Ellul, 774 F.3d at 802 (affirming dismissal where plaintiffs did not allege any
    misrepresentations made by defendants and relied upon by plaintiffs in delaying
    suit); see also Lantzy v. Centex Homes, 73 P.3d at 533 (rejecting equitable estoppel
    argument where ʺcomplaint [was] devoid of any indication that defendantsʹ
    conduct actually and reasonably induced plaintiffs to forbear suingʺ).  They
    simply allege that Kleinhandler failed to inform them of Fredericaʹs death when
    he had a duty to do so.  Simply failing to disclose the fact that Frederica died is
    insufficient for relief under an equitable estoppel theory.   Moreover, even if
    Kleinhandler represented to law enforcement officials that he was authorized to
    act on behalf of the Estate, the Theas did not ascertain this fact until after the
    commencement of this action.  Therefore, his representation to law enforcement
    officials could not have directly and reasonably induced them to forbear from
    bringing suit.
    Finally, due diligence on the part of a plaintiff is a prerequisite to
    equitable estoppel.  See Bernson v. Browning‐Ferris Indus. Of California, Inc., 7 Cal.
    4th 926, 936, (1994) (ʺThe rule of equitable estoppel includes, of course, the
    requirement that the plaintiff exercise reasonable diligence.ʺ).  The proposed
    ‐23‐
    second amended complaint does not even assert when the Theas learned of their
    stepmotherʹs death, and it does not allege any facts to show that they acted
    diligently in the seventeen months between Fredericaʹs death on February 4, 2012
    and their commencement of this action on July 15, 2013.  Indeed, it does not
    appear that they made any effort to call, write, email, visit, or otherwise contact
    Frederica in that time.
    We conclude that the facts alleged in the proposed second amended
    complaint, even if accepted as true, are insufficient to plausibly plead equitable
    estoppel.  Accordingly, Kleinhandler is not precluded from invoking the statute
    of limitations as a defense.
    CONCLUSION
    For the reasons set forth above, the order of the district court is
    AFFIRMED.
    ‐24‐
    

Document Info

Docket Number: 14-3201

Filed Date: 11/3/2015

Precedential Status: Precedential

Modified Date: 11/3/2015

Authorities (20)

Hutchison v. Deutsche Bank Securities Inc. , 647 F.3d 479 ( 2011 )

Mark B. Pangburn v. James Culbertson, Court Clerk John M. ... , 200 F.3d 65 ( 1999 )

Anderson News, L.L.C. v. American Media, Inc. , 680 F.3d 162 ( 2012 )

Staehr v. Hartford Financial Services Group, Inc. , 547 F.3d 406 ( 2008 )

a-michael-sista-plaintiff-appellant-cross-appellee-v-cdc-ixis-north , 445 F.3d 161 ( 2006 )

james-h-gorman-jr-edgardo-carballo-craig-m-cuvelier-frederick-j , 488 F.3d 586 ( 2007 )

Lantzy v. Centex Homes , 2 Cal. Rptr. 3d 655 ( 2003 )

Bernson v. Browning-Ferris Industries of California, Inc. , 7 Cal. 4th 926 ( 1994 )

Prudential-LMI Commercial Insurance v. Superior Court , 51 Cal. 3d 674 ( 1990 )

linda-buttry-and-richard-lacey-v-general-signal-corporation-new-york-air , 68 F.3d 1488 ( 1995 )

brian-keith-stuart-a-minor-by-his-natural-guardian-and-next-friend-pamela , 158 F.3d 622 ( 1998 )

Global Financial Corp. v. Triarc Corp. , 93 N.Y.2d 525 ( 1999 )

Insurance Co. of North America v. ABB Power Generation, Inc. , 91 N.Y.2d 180 ( 1997 )

cantor-fitzgerald-incorporated-a-nevada-corporation-iris-cantor , 313 F.3d 704 ( 2002 )

Klaxon Co. v. Stentor Electric Manufacturing Co. , 61 S. Ct. 1020 ( 1941 )

Erie Railroad v. Tompkins , 58 S. Ct. 817 ( 1938 )

Smith Barney, Harris Upham & Co. v. Luckie , 85 N.Y.2d 193 ( 1995 )

Hanna v. Plumer , 85 S. Ct. 1136 ( 1965 )

Bell Atlantic Corp. v. Twombly , 127 S. Ct. 1955 ( 2007 )

Ashcroft v. Iqbal , 129 S. Ct. 1937 ( 2009 )

View All Authorities »