Puddu v. 6D Global Techs., Inc. ( 2018 )


Menu:
  •      17‐938‐cv
    Puddu v. 6D Global Techs., Inc.
    UNITED STATES COURT OF APPEALS
    FOR THE SECOND CIRCUIT
    SUMMARY ORDER
    RULINGS  BY  SUMMARY  ORDER  DO  NOT  HAVE  PRECEDENTIAL  EFFECT.
    CITATION TO A SUMMARY ORDER FILED ON OR AFTER JANUARY 1, 2007 IS
    PERMITTED  AND  IS  GOVERNED  BY  FEDERAL  RULE  OF  APPELLATE
    PROCEDURE  32.1  AND  THIS  COURT’S  LOCAL  RULE  32.1.1.    WHEN  CITING  A
    SUMMARY  ORDER  IN  A  DOCUMENT  FILED  WITH  THIS  COURT,  A  PARTY
    MUST CITE EITHER THE FEDERAL APPENDIX OR AN ELECTRONIC DATABASE
    (WITH  THE  NOTATION  “SUMMARY  ORDER”).    A  PARTY  CITING  TO  A
    SUMMARY  ORDER  MUST  SERVE  A  COPY  OF  IT  ON  ANY  PARTY  NOT
    REPRESENTED BY COUNSEL.
    1         At a stated term of the United States Court of Appeals for the Second Circuit,
    2   held at the Thurgood Marshall United States Courthouse, 40 Foley Square, in the
    3   City of New York, on the 2nd day of August, two thousand eighteen.
    4
    5         PRESENT:  PIERRE N. LEVAL,
    6                          GUIDO CALABRESI,
    7                          JOSÉ A. CABRANES,
    8                                  Circuit Judges.
    9         ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
    10
    11         JOSEPH PUDDU, MARK GHITIS, VALERY BURLAK, ADAM BUTTER,
    12
    13                                          Plaintiffs‐Appellants,
    14
    15                                  and                                        No. 17‐938‐cv
    16
    17         SIXTO CASTILLO, IV, Individually and on Behalf
    18         of All Others Similarly Situated,
    19
    20                                          Plaintiff,
    21
    22                                  v.
    1
    1         6D GLOBAL TECHNOLOGIES, INC., TEJUNE
    2         KANG, MARK SZYNKOWSKI, TERRY
    3         MCEWEN,
    4
    5                                          Defendants‐Appellees,
    6
    7                                  and
    8
    9         NEW YORK GLOBAL GROUP, INC., NYGG
    10         (ASIA), LTD., BENJAMIN TIANBING WEI, AKA
    11         BENJAMIN WEY, ADAM HARTUNG, DAVID S.
    12         KAUFMAN, ANUBHAV SAXENA, ADAM
    13         WARE, BRIAN WARNER, DAVID SLOVINA,
    14         GERARD CASAZZA, HILARY SMITH, JASON
    15         PORATH, KAT TOPAZ, MIKE TELATOVICH,
    16         TANDY HARRIS, RAY ROBINSON, TJ
    17         IACIOFANO, BEI LU, NAN LIU, DAINFU LU,
    18         ARNOLD STALOFF, SHUYUAN LIU, ZILI
    19         ZHAO, SEREF DOGAN ERBEK, TIANYI WEI,
    20         AKA SARA WEI, MICHAELA WEI, ROBERT
    21         NEWMAN, SHENG MA, FEGJUN SUN, NYG
    22         CAPITAL LLC,
    23
    24                                          Defendants.
    25
    26         ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
    27
    28         FOR APPELLANTS:                                   LAURENCE M. ROSEN, The Rosen Law
    29                                                                   Firm, P.A., New York, N.Y.
    30
    31         FOR APPELLEES:                                    TOM M. FINI, Catafago Fini LLP, New
    32                                                                   York, N.Y.
    33
    34         Appeal from a March 6, 2017 judgment of the United States District Court
    35   for the Southern District of New York (Robert W. Sweet, Judge).
    2
    1         UPON DUE CONSIDERATION, it is hereby ORDERED, ADJUDGED,
    2   AND DECREED that the March 6, 2017 judgment of the District Court is
    3   VACATED in part and the case is REMANDED for further proceedings.
    4         Plaintiff‐Appellants Joseph Puddu, Mark Ghitis, Valery Burlak, and Adam
    5   Butter (“Plaintiffs”) appeal from the judgment of the United States District Court
    6   for the Southern District of New York dismissing their Second Amended
    7   Complaint (the “Complaint”) for failure to state a claim pursuant to Federal Rule
    8   of Civil Procedure 12(b)(6). Plaintiffs, former shareholders of 6D Global
    9   Technologies (“6D”), brought claims on behalf of a putative class of all persons
    10   and entities who purchased the common stock of 6D from June 16, 2014 to
    11   September 10, 2015 or in a private placement taking place on September 29, 2014
    12   and November 21, 2014. Defendant‐Appellees are 6D and three of its officers and
    13   directors: CEO Tejune Kang, CFO Mark Szynkowski, and director Terry McEwen
    14   (“Defendants”). The Complaint alleges that Defendants committed securities
    15   fraud in violation of Sections 10(b) and 20(a) of the Securities Exchange Act of
    16   1934, 15 U.S.C. §§ 78j(b), 78t(a), and Rule 10b‐5, 17 C.F.R. § 240.10b‐5, by failing to
    17   disclose that Benjamin Wey, an indicted fraudulent manipulator of securities,
    3
    1   was a “beneficial owner” of 6D.1  We assume the parties’ familiarity with the
    2   underlying facts, procedural history, and the issues on appeal.
    3         We review a Rule 12(b)(6) dismissal de novo, “accepting all factual
    4   allegations in the complaint and drawing all reasonable inferences in the
    5   plaintiff’s favor.” ATSI Commc’ns, Inc. v. Shaar Fund, Ltd., 493 F.3d 87, 98 (2d Cir.
    6   2007). “To survive a motion to dismiss, a complaint must contain sufficient
    7   factual matter, accepted as true, to state a claim for relief that is plausible on its
    8   face.” Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662, 678 (2009) (internal quotation marks
    9   omitted). Securities fraud claims must also satisfy the pleading requirements of
    10   Federal Rule of Civil Procedure 9(b) and the Private Securities Litigation Reform
    11   Act, 15 U.S.C. § 78u‐4(b) (“PLSRA”). ATSI, 493 F.3d at 99.
    12         To state a claim under Section 10(b) and Rule 10b‐5, “a plaintiff must allege
    13   that the defendant (1) made misstatements or omissions of material fact, (2) with
    14   scienter, (3) in connection with the purchase or sale of securities, (4) upon which
    1  The Complaint also alleges that Defendants committed securities fraud by
    failing to disclose, in 6D’s bylaws, that Wey was 6D’s “unofficial CEO.” Joint
    Appendix (“App.”) at 29. Plaintiffs do not appeal the District Court’s dismissal of
    that claim.
    4
    1   the plaintiff relied, and (5) that the plaintiff’s reliance was the proximate cause of
    2   its injury.” Id. at 105. The District Court dismissed Plaintiffs’ claims for failure to
    3   adequately plead a material misstatement or omission, scienter, and proximate
    4   cause. Because we hold that Plaintiffs adequately pled all three of these elements,
    5   we vacate the judgment (except as to Defendant McEwen, whose dismissal we
    6   affirm) and remand for further proceedings.
    7       I. Material Misstatement or Omission
    8          The Complaint adequately alleges that Defendants made misstatements or
    9   omissions of material fact during the class period. The Complaint alleges that
    10   Wey, the CEO of the financial consulting firm New York Global Group
    11   (“NYGG”) who in 2015 was indicted for securities fraud, exerted near‐complete
    12   control over New York Global Group‐Asia (“NYGG‐Asia”), a Beijing‐based firm
    13   that owned approximately 45% of the outstanding shares of 6D’s common stock.
    14   Through his control over NYGG‐Asia, the Complaint alleges, Wey “beneficially
    15   owned” more than 5% of the securities of 6D. SEC regulations define a
    16   “beneficial owner” as a person who “directly or indirectly, through any contract,
    17   arrangement, understanding, relationship, or otherwise has or shares” voting
    5
    1   power or investment power over a security. 17 C.F.R. § 240.13d‐3(a). Issuers are
    2   required to disclose the beneficial owners of more than 5% of their securities. 17
    3   C.F.R. § 229.403(a). Accordingly, the Complaint alleges, 6D was required, but
    4   failed, to disclose Wey’s beneficial ownership of 45% of the common stock of 6D.
    5         Defendants argue Wey’s beneficial ownership of 6D was inadequately
    6   pled. We disagree. The Complaint contains numerous fact‐based allegations
    7   which, taken together, plausibly allege that Wey exerted near‐complete control
    8   over NYGG‐Asia and that he was treated, by 6D executives, as a powerful
    9   shareholder of 6D. For example, the Complaint alleges that Kang told another 6D
    10   executive that Wey was “a shareholder” of 6D and that “he’s got influence.”
    11   App. at 30. The Complaint also alleges that, in a sworn affidavit submitted in
    12   connection with another litigation (the “Discover Litigation”), the principal of
    13   Discover Growth Fund (“Discover”) testified that Kang and Szynkowski referred
    14   to NYGG‐Asia and Wey interchangeably as the holder of 45% of 6D stock. The
    15   Complaint further alleges that in another sworn declaration submitted in the
    16   Discover Litigation, a Discover manager asserted that Kang introduced Wey as
    17   6D’s controlling stockholder saying, “basically, I work for him.” Id. at 57. The
    6
    1   Complaint refers to, and incorporates by reference, a September 2015 SEC
    2   complaint against Wey, which alleges that Wey owned and controlled NYGG‐
    3   Asia.
    4          These allegations, taken together and accepted as true, permit the inference
    5   that Wey had the power to direct the voting and/or disposition (i.e., that he was a
    6   “beneficial owner”) of NYGG‐Asia’s shares in 6D. The District Court, in
    7   concluding that the allegations were merely conclusory, failed—as required on a
    8   Rule 12(b)(6) motion to dismiss—to “draw[] all reasonable inferences in the
    9   plaintiff’s favor.” ATSI, 493 F.3d at 98. Properly construed on a 12(b)(6) motion,
    10   the Complaint plausibly alleges that Defendants failed to disclose Wey’s
    11   beneficial ownership of 6D.
    12       II. Scienter
    13          The Complaint also adequately alleges that Defendants acted with scienter.
    14   To adequately plead scienter under the PLSRA, a complaint must “state with
    15   particularity facts giving rise to a strong inference that the defendant acted with
    16   the required state of mind.” 15 U.S.C. § 78u‐4(b)(2)(A). “The requisite scienter can
    17   be established by alleging facts to show either (1) that defendants had the motive
    7
    1   and opportunity to commit fraud, or (2) strong circumstantial evidence of
    2   conscious misbehavior or recklessness.” ECA v. JP Morgan Chase Co., 553 F.3d
    3   187, 198 (2d Cir. 2009).
    4         The Complaint alleges that Kang and Szynkowski, despite privately
    5   acknowledging Wey’s influence over 6D, publicly denied Wey’s involvement in
    6   the company. For example, the Complaint states that in December 2014, Kang
    7   instructed 6D executives not to mention Wey in emails, or if they had to, to use a
    8   code name. The Complaint alleges that Kang lied to the 6D Board of Directors
    9   about Wey’s involvement in 6D. It alleges that Kang and Szynkowski, in sworn
    10   declarations submitted in the Discover Litigation, claimed that Wey was not a
    11   shareholder of 6D. The Complaint alleges that Szynkowski further swore that
    12   Wey was merely “an occasional unpaid consultant to 6D Global.” App. at 74.
    13   Meanwhile, the Complaint alleges, Kang and Szynkowski privately referred to
    14   Wey and NYGG‐Asia interchangeably as the 45% shareholder of 6D. These
    15   allegations, taken as true, strongly imply that Kang and Szynkowski
    16   intentionally concealed Wey’s involvement in 6D. They allege “strong
    17   circumstantial evidence of conscious misbehavior or recklessness.” ECA, 553 F.3d
    8
    1   at 198. Therefore, the Complaint adequately pled scienter as to Defendants Kang
    2   and Szynkowski.2
    3       III.     Loss Causation
    4          Finally, the Complaint adequately pleads loss causation. The Complaint’s
    5   theory of causation is that once Wey’s involvement in NYGG‐Asia was revealed
    6   (on September 10, 2015, when an SEC complaint and DOJ indictment against
    7   Wey became public), NASDAQ halted trading of, and eventually delisted, 6D
    8   stock. When the stock resumed trading over the counter, its price fell rapidly,
    9   causing Plaintiffs’ loss. The District Court rejected Plaintiffs’ theory. It found that
    10   the alleged omission could not have caused the loss in value of 6D’s stock,
    11   because the purported corrective disclosures—the DOJ indictment and SEC
    12   complaint—did not disclose that Wey controlled NYGG‐Asia, much less that he
    13   was a beneficial owner of 6D.
    14          We believe this was error. The September 10, 2015 SEC complaint alleged
    15   that Wey “ran” NYGG‐Asia, and that the head of NYGG‐Asia was Wey’s sister’s
    2 With respect to Defendant McEwen, the Complaint is devoid of factual
    allegations that could support a plausible inference of scienter. We therefore
    affirm the District Court’s dismissal of the Complaint with respect to McEwen.
    9
    1   domestic partner, who “reported to Benjamin Wey.” App. at 135. The SEC
    2   complaint further alleged that Wey had lied about his control over NYGG‐Asia,
    3   falsely claiming in a letter to NASDAQ that NYGG and NYGG‐Asia were
    4   “separately owned and operated.” Id. at 134. The SEC complaint thus did allege
    5   that Wey exerted substantial control over NYGG‐Asia, and Plaintiffs’ Complaint
    6   alleges that this disclosure caused NASDAQ to halt trading in 6D’s shares.
    7         The District Court held that causation was inadequately pled, in part
    8   because 6D’s stock price did not decline until six months after the release of the
    9   SEC complaint. This was error. 6D stock was not traded during those six months,
    10   pending 6D’s appeal of the NASDAQ delisting. The Complaint alleges that once
    11   6D trading resumed over the counter, its stock value declined from $2.90 to $0.21
    12   over the course of four days. The District Court also held that causation was
    13   inadequately pled because the resignation of 6D’s auditor, rather than the
    14   revelation of Wey’s involvement in NYGG‐Asia, may have caused 6D’s delisting.
    15   We disagree. NASDAQ’s delisting letter indicates that concerns over Wey’s
    16   involvement in 6D substantially contributed to the delisting of 6D’s stock, even if
    17   the auditor’s resignation was the final straw.
    10
    1         We have considered Defendants’ remaining arguments and conclude that
    2   they are without merit. The judgment of the District Court dismissing the
    3   Complaint is VACATED, except as to Defendant McEwen, as to whom the
    4   dismissal is AFFIRMED, and the case is REMANDED for further proceedings.
    5                                        FOR THE COURT:
    6                                        Catherine O’Hagan Wolfe, Clerk of Court
    11
    

Document Info

Docket Number: 17-938-cv

Filed Date: 8/2/2018

Precedential Status: Non-Precedential

Modified Date: 8/2/2018